Datos de identificaciónofrecida por:
Situación de la empresa | Activa |
CIF/NIF | A81787889 |
Número D-U-N-S | 565139243 |
Denominación | REALIA BUSINESS SA |
Denominación | REALIA BUSINESS |
Domicilio Social | AVENIDA CAMINO DE SANTIAGO, 40 - 6 - 28050 MADRID (Madrid) |
Domicilio Anterior | PASEO CASTELLANA (PTA. DE EUROPA), 216 - 28046 MADRID (Madrid) |
Telefono | 913534400 |
Fax | 913534417 |
Email corporativo | accionistas@realia.es |
Estructura legalofrecida por:
Forma Juridica | Sociedad anónima |
Capital social | 196.863.767,52 € |
Capital social desembolsado | 196.863.767,52 € |
Cotiza en bolsa | SI |
Obligado a presentar cuentas | SI |
Censo cameral | 2021 |
Información financieraofrecida por:
Ventas Ultimo Años | 26.552.000,00 € (año 2020 - Registro Mercantil) |
Resultado Ultimo Año | -9.751.000,00 € (año 2020 - Registro Mercantil) |
Total Activo | 621.552.000,00 € (año 2020 - Registro Mercantil) |
Años elementos financieros | 2020 |
Información comercialofrecida por:
Fecha de constitucion | 14/08/1997 |
Actividad Informa | 1833000 - Promoción inmobiliaria |
CNAE 2009 | 4110 - Promoción inmobiliaria |
Codigo CNAE 2009 | 4110 |
SIC | 1531 - Promotores de obras |
Objeto social | LA ADQUISICION, ENAJENACION, GRAVAMEN, ARRENDAMIENTO, ADMINISTRACION, PROMOCION, CONSTRUCCION, URBANIZACION, PARCELACION Y EXPLOTACION, POR CUALQUIER TITULO ADMITIDO EN DERECHO DE BIENES INMUEBLES, RUSTICOS O URBANOS ETC |
Numero de empleados | 39 (año 2020) |
Actividad Internacional | No constan |
Otra información de interésofrecida por:
Fecha Ultima Actualizacion | 03/03/2022 |
Balance disponible | 2014 |
Fecha Ultima Investigacion | 15/07/2015 |
Deposito Registro Mercantil | 2020 |
Estructura corporativa
Resumen
Cargos no vigentes | 201 miembros (19/08/2021) |
Otros cargos | 36 miembros (07/01/2022) |
Órgano de administración | 17 miembros (19/08/2021) |
Auditores de cuentas | 2 miembros (07/06/2017) |
Directivos funcionales | 3 miembros (27/03/2013) |
Órgano de administraciónofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Presidente | BAYON MARINE, IGNACIO | 25/07/2007 |
Presidente | RODRIGUEZ TORRES, JUAN | 10/11/2015 |
Consejero Delegado | KURI KAUFFMANN, GERARDO | 09/10/2015 |
Consejero Delegado | KURI KAUFMANN, GERARDO | 10/11/2015 |
Consejero | ALCOCER KOPLOWITZ, ESTHER | 19/08/2021 |
Consejero | ALCOCER KOPOLWITZ, ALICIA | 19/08/2021 |
Consejero | ALDAZ BARRERA, IÑIGO | 23/05/2007 |
Consejero | CARAZA CAMPOS, XIMENA | 11/06/2019 |
Consejero | CARTERA DEVA SA | 29/10/2009 |
Consejero | EAC INVERSIONES CORPORATIVAS SL | 23/05/2007 |
Consejero | EAC INVERSIONES CORPORATIVAS SL REPRES PJ ESTHER ALCOCER KOPLOWITZ | 31/08/2012 |
Consejero | FALCO Y FERNANDEZ DE CORDOVA, FERNANDO | 23/05/2007 |
Consejero | FERERES CASTIEL, ELIAS | 11/06/2019 |
Consejero | IGLESIAS CANO, CARMEN | 23/05/2007 |
Consejero | INMOGESTION Y PATRIMONIOS SA | 29/10/2009 |
Consejero | LINARES LIEBANA, MARIA ANTONIA | 27/07/2011 |
Consejero | MAS MILLET, JOSE MARIA | 23/05/2007 |
Consejero | MEDIACION Y DIAGNOSTICOS SA | 23/05/2007 |
Consejero | MELILOTO SL REPRES PJ ALICIA ALCOCER KOPLOWITZ | 31/08/2012 |
Consejero | MONTES SANCHEZ, RAFAEL | 23/05/2007 |
Consejero | PARTICIPACIONES Y CARTERA DE INVERSION SL | 23/05/2007 |
Consejero | TRUEBA GUTIERREZ, JOSE EUGENIO | 23/05/2007 |
Consejero | VALORACION Y CONTROL S L | 23/05/2007 |
Directivos funcionalesofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Director/Responsable de Calidad | PRIETO PEÑA, MARIA | 27/04/2005 |
Director/Responsable de Marketing | PRIETO PEÑA, MARIA | 27/04/2005 |
Director/Responsable Financiero | FRANCO, JUAN ANTONIO | 27/03/2013 |
Director Financiero | FRANCO, JUAN ANTONIO | 27/03/2013 |
Director General | ALDAZ BARRERA, INIGO MARIA | 07/11/2001 |
Director de Marketing | PRIETO PE, A. MARIA | 27/04/2005 |
Director de Marketing | PRIETO PEÑA, MARIA | 27/04/2005 |
Director de Calidad | PRIETO PE, A. MARIA | 27/04/2005 |
Director de Calidad | PRIETO PEÑA, MARIA | 27/04/2005 |
Auditores de cuentasofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Auditor | DELOITTE SL | 18/11/2011 |
Auditor | ERNST & YOUNG SL | 07/06/2017 |
Auditor Cuentas Consolidadas | DELOITTE & TOUCHE ESPAÑA SOCIEDAD LIMITADA EN LA A | 16/11/2011 |
Auditor Cuentas Consolidadas | DELOITTE SL | 16/11/2011 |
Auditor Cuentas Consolidadas | ERNST & YOUNG SL | 07/06/2017 |
Remuneración del consejo
Fuente | 2010 |
Importe | 2575000 |