Datos de identificaciónofrecida por:
Situación de la empresa | Extinción (26/10/2016) |
CIF/NIF | A28017804 |
Número D-U-N-S | 466956232 |
Denominación | METROVACESA SA (EXTINGUIDA) |
Denominación | GESINAR SERVICIOS INMOBILIARIOS |
Domicilio Social | CALLE QUINTANAVIDES (PQ. METROVACESA VIA NORTE), 13 - 28050 MADRID (Madrid) |
Domicilio Anterior | PLAZA CARLOS TRIAS BERTRAN, 7 - 6ª PLT - 28020 MADRID (Madrid) |
Telefono | 913185542 |
Fax | 915567298 |
URL | www.metrovacesa.com |
Email corporativo | csanchez@metrovacesa.es |
Estructura legalofrecida por:
Forma Juridica | Sociedad anónima |
Capital social | 768.819.538,51 € |
Capital social desembolsado | 674.307.899,33 € |
Cotiza en bolsa | NO |
Obligado a presentar cuentas | SI |
Censo cameral | 2010 |
Información financieraofrecida por:
Ventas Ultimo Años | 123.289.000,00 € (año 2015 - Registro Mercantil) |
Resultado Ultimo Año | -64.113.000,00 € (año 2015 - Registro Mercantil) |
Total Activo | 4.381.385.000,00 € (año 2015 - Registro Mercantil) |
Años elementos financieros | 2015 |
Información comercialofrecida por:
Fecha de constitucion | 27/03/1935 |
Actividad Informa | 1833000 - Promoción inmobiliaria |
CNAE 2009 | 6810 - Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia |
Codigo CNAE 2009 | 6810 |
SIC | 6531 - Agencias inmobiliarias, administradores de fincas |
Objeto social | ADQUISICION O CONSTRUCCION DE TODA CLASE DE FINCAS PARA SU EXPLOTACION EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO O EN CUALQUIER OTRO QUE PERMITA EL ORDENAMIENTO JURIDICO. PROMOCION, URBANIZACION Y PARCELACION DE BIENES INMUEBLES EN GN |
Numero de empleados | 154 (año 2015) |
Actividad Internacional | Exporta |
Otra información de interésofrecida por:
Fecha Ultima Actualizacion | 02/03/2022 |
Balance disponible | 2013 |
Fecha Ultima Investigacion | 06/05/2013 |
Deposito Registro Mercantil | 2015 |
Estructura corporativa
Resumen
Cargos no vigentes | 381 miembros (26/10/2016) |
Órgano de administración | 12 miembros (06/05/2015) |
Otros cargos | 33 miembros (25/07/2014) |
Auditores de cuentas | 2 miembros (18/01/2012) |
Directivos funcionales | 1 miembros (06/05/2015) |
Órgano de administraciónofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Presidente | ECHENIQUE GORDILLO, RODRIGO | 06/05/2015 |
Presidente | MORENO MARTINEZ, IGNACIO | 10/12/2012 |
Consejero Delegado | GARCIA LEON, CARLOS | 16/04/2013 |
Consejero Delegado | MORENO MARTINEZ, IGNACIO | 06/05/2015 |
Consejero Delegado | PARAJA QUIROS, EDUARDO HORACIO | 21/09/2009 |
Consejero | ANDRES YANES, JUAN | 25/02/2009 |
Consejero | BEJAR GONZALEZ, ANTONIO JOSE | 14/08/2009 |
Consejero | CAJA AHORROS EL MONTE REPRES PJ BUENO LIDON JOSE MARIA | 30/06/2003 |
Consejero | CASTRO ALADRO, MANUEL | 28/04/2015 |
Consejero | EXPO AN REPRES PJ PORTILLO MUNOZ LUIS MANUEL | 30/06/2003 |
Consejero | FERNANDEZ CONQUERO, JOSE MARIA | 29/06/2010 |
Consejero | GARCIA CARRANZA BENJUMEA, FRANCISCO JAVIER | 29/02/2016 |
Consejero | IGLESIAS SURRIBAS, REMIGIO | 13/06/2011 |
Consejero | JIMENEZ DELGADO, JUAN | 03/11/2009 |
Consejero | MARCO GARDOQUI IBANEZ, JOSE RAMON | 30/03/2001 |
Consejero | MATUTES JUAN, ABEL | 28/04/2015 |
Consejero | MUNIZ GONZALEZ BLANCH, CARLOS | 29/09/2009 |
Consejero | ORTEGA HERNANDEZ AGERO, FRANCISCA | 22/11/2013 |
Consejero | RUIZ DE ALDA MORENO, JUAN IGNACIO | 28/04/2015 |
Consejero | SACRESA TERRENOS PROMOCION SL REPRES PJ USANDIZAGA USANDIZAGA PABLO | 18/07/2007 |
Consejero | SAENZ DE TEJADA PULIDO, JAIME | 19/11/2015 |
Consejero | VIDAL ARAGON DE OLIVES, AGUSTIN | 27/11/2014 |
Consejero | VILLALABEITIA GALARRAGA, GREGORIO | 06/02/2003 |
Secretario | OSORIO ITURMENDI, LUCAS | 26/05/2009 |
Directivos funcionalesofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Director Financiero | MORENO, JAVIER | 06/10/2005 |
Director General | GARCÍA LEÓN, CARLOS | 06/05/2015 |
Director de Marketing | ESPINOSA, RUBEN | 06/10/2005 |
Director de Informática | VICENTE ASENJO, JESUS | 06/10/2005 |
Auditores de cuentasofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Auditor | DELOITTE SL | 17/08/2009 |
Auditor Cuentas Consolidadas | DELOITTE SL | 18/01/2012 |
Remuneración del consejo
Fuente | 2011 |
Importe | 728000 |