Datos de identificaciónofrecida por:
Situación de la empresa | Activa |
CIF/NIF | A28212264 |
Número D-U-N-S | 462007212 |
Denominación | ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA. |
Denominación | TISU DE LOURIZAN |
Domicilio Social | CALLE BEATRIZ DE BOBADILLA, 14 - PLT 4 - 28040 MADRID (Madrid) |
Domicilio Anterior | PASEO CASTELLANA, 35 - PRIMERA PLANTA - 28046 MADRID (Madrid) |
Telefono | 913378500 |
Fax | 913378556 |
URL | www.ence.es |
Email corporativo | es@ence.es |
Estructura legalofrecida por:
Forma Juridica | Sociedad anónima |
Capital social | 221.645.250 € |
Capital social desembolsado | 221.645.250 € |
Cotiza en bolsa | SI |
Obligado a presentar cuentas | SI |
Censo cameral | 2021 |
Información financieraofrecida por:
Ventas Ultimo Años | 344.819.000,00 € (año 2020 - Registro Mercantil) |
Resultado Ultimo Año | 64.773.000,00 € (año 2020 - Registro Mercantil) |
Total Activo | 1.290.585.000,00 € (año 2020 - Registro Mercantil) |
Años elementos financieros | 2020 |
Información comercialofrecida por:
Fecha de constitucion | 21/12/1968 |
Actividad Informa | 1471000 - Fabricación de pasta papelera |
CNAE 2009 | 1711 - Fabricación de pasta papelera |
Codigo CNAE 2009 | 1711 |
SIC | 2611 - Fabricas de pulpa (pasta de papel) |
Objeto social | LA FABRICACION DE PASTAS Y DERIVADOS DE ESTAS, OBTENCION DE PRODUCTOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA AQUELLAS Y APROVECHAMIENTO DE LOS SUBPRODUCTOS RESULTANTES DE UNA Y OTRA. |
Numero de empleados | 537 (año 2020) |
Actividad Internacional | Exporta |
Otra información de interésofrecida por:
Fecha Ultima Actualizacion | 04/03/2022 |
Balance disponible | 2014 |
Fecha Ultima Investigacion | 13/07/2021 |
Deposito Registro Mercantil | 2020 |
Estructura corporativa
Resumen
Cargos no vigentes | 238 miembros (05/11/2021) |
Órgano de administración | 20 miembros (04/06/2021) |
Otros cargos | 81 miembros (05/11/2021) |
Auditores de cuentas | 2 miembros (26/05/2021) |
Directivos funcionales | 3 miembros (25/09/2020) |
Órgano de administraciónofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Presidente | ARREGUI CIARSOLO, JUAN LUIS | 27/07/2009 |
Presidente | DE COLMENARES BRUNET, IGNACIO | 13/04/2020 |
Consejero Delegado | DE COLMENARES Y BRUNET, IGNACIO | 20/01/2011 |
Vicepresidente | DE COLMENARES BRUNET, IGNACIO | 15/07/2014 |
Consejero | ABRIL MARTORELL HERNANDEZ, FERNANDO | 19/08/2010 |
Consejero | ALVAREZ LOPEZ, ENRIQUE | 04/08/2006 |
Consejero | ARREGUI ABENDIVAR, GORKA | 04/06/2021 |
Consejero | ARREGUI ABENDIVAR, JAVIER | 04/06/2021 |
Consejero | ARREGUI ABENDIVAR, OSCAR | 04/06/2021 |
Consejero | BARATO TRIGUERO, PEDRO | 17/12/2008 |
Consejero | COMENGE Y SANCHEZ REAL, JOSE IGNACIO | 09/02/2021 |
Consejero | DEL ALAMO JIMENEZ JOSE, ANTONIO CARLOS | 27/07/2009 |
Consejero | DEL ALAMO JIMENEZ, JOSE CARLOS | 01/05/2019 |
Consejero | ECHENIQUE LANDIRIBAR, JAVIER | 27/07/2009 |
Consejero | FERNANDEZ MARTINEZ, PASCUAL | 17/12/2008 |
Consejero | GOROSTIZA TELLERIA, AMAIA | 17/06/2019 |
Consejero | HERNANDEZ ALVAREZ, IRENE | 17/06/2019 |
Consejero | NORTEÑA PATRIMONIAL SL | 17/12/2008 |
Consejero | PALACIOS ESTEBAN, ANTONIO | 17/11/2008 |
Consejero | RETOS OPERATIVOS XXI SL | 27/07/2009 |
Consejero | ROBINA ROSAT, MARIA DE LA PAZ | 26/03/2021 |
Consejero | ROBINA ROSAT, MARIA PAZ | 04/06/2021 |
Consejero | SERRA PERIS, JOSE MANUEL | 17/12/2008 |
Consejero | ZUBIA GUINEA, JOSE GUILLERMO | 19/08/2010 |
Directivos funcionalesofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Director/Responsable Financiero | AVELLO, ALFREDO | 25/09/2020 |
Director Financiero | MAUS LIZARITURRY, DIEGO | 07/06/2009 |
Director General | AGUILO JUBIERRE, JORDI | 15/02/2020 |
Director General | ARREGUI CIARSOLO, JUAN LUIS | 27/04/2006 |
Director Comercial | PEROJO, HUGO | 30/01/2008 |
Director Comercial | WIRÉN, MIKAEL | 22/05/2014 |
Director de Marketing | WIRÉN, MIKAEL | 22/05/2014 |
Director RRHH | ZUERAS MARIA, JOSE | 30/01/2008 |
Director de Operaciones | ARGUELLES, JAIME | 03/01/2011 |
Auditores de cuentasofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Auditor | KPMG AUDITORES SL | 26/05/2021 |
Auditor | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | 09/06/2011 |
Auditor Cuentas Consolidadas | KPMG AUDITORES SL | 26/05/2021 |
Auditor Cuentas Consolidadas | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | 09/06/2011 |
Remuneración del consejo
Fuente | 2011 |
Importe | 937000 |