Datos de identificaciónofrecida por:
Situación de la empresa | Activa |
CIF/NIF | A08049793 |
Número D-U-N-S | 460014376 |
Denominación | URBAS GRUPO FINANCIERO SA. |
Domicilio Social | CALLE GOBELAS, 15 - 28023 MADRID (Madrid) |
Domicilio Anterior | CALLE SANTA CRUZ DE MARCENADO, 4 - BJ LOC 10 - 28015 MADRID (Madrid) |
Telefono | 915633950 |
Fax | 949217428 |
URL | www.grupourbas.com |
Email corporativo | info@grupourbas.com |
Estructura legalofrecida por:
Forma Juridica | Sociedad anónima |
Capital social | 434.511.277,37 € |
Capital social desembolsado | 434.511.277,37 € |
Cotiza en bolsa | SI |
Obligado a presentar cuentas | SI |
Censo cameral | 2021 |
Información financieraofrecida por:
Ventas Ultimo Años | 4.994.000,00 € (año 2020 - Registro Mercantil) |
Resultado Ultimo Año | 5.745.000,00 € (año 2020 - Registro Mercantil) |
Total Activo | 486.624.000,00 € (año 2020 - Registro Mercantil) |
Años elementos financieros | 2020 |
Información comercialofrecida por:
Fecha de constitucion | 20/10/1944 |
Actividad Informa | 1833000 - Promoción inmobiliaria |
CNAE 2009 | 4110 - Promoción inmobiliaria |
Codigo CNAE 2009 | 4110 |
SIC | 1531 - Promotores de obras |
Objeto social | LA ADQUISICION DE TERRENOS Y BIENES INMUEBLES EN GENERAL. EXPLOTACION DE NEGOCIOS RELACIONADOS CON EL SECTOR ENERGETICO. |
Numero de empleados | 6 (año 2020) |
Actividad Internacional | No constan |
Otra información de interésofrecida por:
Fecha Ultima Actualizacion | 07/03/2022 |
Balance disponible | 2013 |
Fecha Ultima Investigacion | 09/10/2015 |
Deposito Registro Mercantil | 2020 |
Estructura corporativa
Resumen
Cargos no vigentes | 135 miembros (30/04/2021) |
Órgano de administración | 13 miembros (11/11/2021) |
Otros cargos | 14 miembros (27/12/2021) |
Auditores de cuentas | 2 miembros (13/11/2015) |
Directivos funcionales | 1 miembros (08/10/2015) |
Órgano de administraciónofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Presidente | IBANEZ FERNANDEZ, JUAN ANTONIO | 13/11/2009 |
Presidente | QUAMTIUM VENTURE SL REPRES PJ JUAN ANTONIO ACEDO FERNANDEZ | 08/03/2019 |
Presidente | ROBISCO INVESTMENT SL | 11/08/2014 |
Vicepresidente | AURICI DEL SUR SL REPRES PJ MORENO INFANTES JULIA MARIA | 20/07/2013 |
Vicepresidente | CASTELLVI REY, JOAQUIN | 14/07/1994 |
Vicepresidente | QUAMTIUM VENTURE SL | 21/07/2014 |
Consejero | ALONSO VILLALOBOS DE LA VIESCA, IGNACIO | 30/04/2021 |
Consejero | ARAGONES MONJAS, ALBERTO | 11/11/2021 |
Consejero | CASTELLVIGUAL, MIGUEL | 22/09/1993 |
Consejero | CENTRO DE ASESORAMIENTO E INVERSIONES SA | 04/01/1999 |
Consejero | COBO MORAL, PABLO | 25/09/2018 |
Consejero | DE GOUVEIA JOAO, JOSE | 11/11/2021 |
Consejero | F Y F AUDITEX SA | 04/01/1999 |
Consejero | FERNANDEZ CUESTAE ILLANA, NEMESIO | 24/05/1990 |
Consejero | GARCIA DE PONGA, JESUS | 11/11/2021 |
Consejero | GUERRERO HIDALGO, ADOLFO JOSE | 25/09/2018 |
Consejero | MARTIN HERRERO, JESUS MARIA | 24/05/1990 |
Consejero | PENA CARRILLO, JUAN | 04/01/1999 |
Consejero | POLANCO SOUTULLO, JAIME | 11/11/2021 |
Consejero | RAMOS ATIENZA, LUIS | 30/04/2021 |
Consejero | SAIZ RUIZ, PEDRO LUIS | 02/10/1992 |
Consejero | SANZAR ASESORIA SL | 14/10/2019 |
Consejero | SANZAR ASESORIA SL REPRES PJ CHECA ZAVALA IGNACIO MARIA FLORENTINO | 24/09/2015 |
Secretario | CUADRADO LOPEZ, IVAN | 13/11/2009 |
Directivos funcionalesofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Director Financiero | MONDEJAR JOSE, MARIA | 10/03/2005 |
Director General | LAHUERTA TORNOS, ENRIQUE | 07/04/2010 |
Director General | SEVILLA FERNANDEZ, JOSE LUIS | 11/09/2007 |
Gerente | IBAÑEZ FERNANDEZ, JUAN ANTONIO | 08/10/2015 |
Auditores de cuentasofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Auditor | BAKER TILLY AUDITORES SLP | 13/11/2015 |
Auditor | BAKER TILLY FMAC SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL | 13/11/2015 |
Auditor | DELOITTE SL | 21/10/2011 |
Auditor Cuentas Consolidadas | BAKER TILLY AUDITORES SLP | 13/11/2015 |
Auditor Cuentas Consolidadas | BAKER TILLY FMAC SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL | 13/11/2015 |
Auditor Cuentas Consolidadas | DELOITTE SL | 21/10/2011 |
Remuneración del consejo
Fuente | 2010 |
Importe | 132000 |